Clio Holdings Bankruptcy 2020 List of creditors | Page 43

Case 20-10080-BLS Doc 6 Filed 01/17/20 Clio Creditor List.txt Countertop Expressions LLC 3000 Manorview Lane Highland Mills, NY  10930 COUNTRY CLUB BANK CREDIT CARDS Saint Louis, MO  63123 Barbara Emmack Country Meadows Custom Homes LLC 5419 SOUTH JENNINGS COURT Milwaukee, WI  53288‐0001 Countryside Creations LLC Countryside Creations LLC 3319 State Route 14A Johnson City, TN  37604 County of Fairfax ‐ Fire Marshal's Office 12099 Government Ctr Pkwy 3rd Floor Birmingham, AL  35283‐0725 County of York Commissioner of the Revenue PO Box 189 Saint Louis, MI  48880 Rene Kraenzlin Cowen and Company LLC 599 Lexington Ave Mount Pleasant, MI  48858 Cox Business PO Box 248871 Tuscaloosa, AL  35405 Cox Communications ‐ GS DEPT 781114 PO Box 78000 San Francisco, CA  94139‐8897 Coy Brinkley 1960 N. Washington St. Cranbury, NJ  08512 CPJ & Associates ‐ MA Page 43 Page 43 of 332